| John George Rauch, Nellie Catherine Armstrong - 1928 - 128 páginas
...in the said district of Louisiana, at the commencement of this act, and not inconsistent with any of the provisions thereof, shall continue in force until altered, modified, or repealed by the Governor and judges of the Indiana Territory." This authority was to be in force only for one year... | |
| 1931 - 636 páginas
[ Lo sentimos, pero el contenido de esta página es de acceso restringido. ] | |
| Maine - 1939 - 1168 páginas
[ Lo sentimos, pero el contenido de esta página es de acceso restringido. ] | |
| Louisiana - 1951 - 1378 páginas
[ Lo sentimos, pero el contenido de esta página es de acceso restringido. ] | |
| Anna Marie Keppel - 1954 - 534 páginas
[ Lo sentimos, pero el contenido de esta página es de acceso restringido. ] | |
| 1957 - 406 páginas
[ Lo sentimos, pero el contenido de esta página es de acceso restringido. ] | |
| United States - 1961 - 910 páginas
[ Lo sentimos, pero el contenido de esta página es de acceso restringido. ] | |
| 1902 - 272 páginas
...Section 16 of the Act provided: "That the laws and regulations in force in the Territory of Louisiana at the commencement of this act and not inconsistent...force until altered, modified, or repealed by the General Assembly." On January 19, 1816, the Legislature of the Territory of Missouri enacted a statute... | |
| 1902 - 276 páginas
[ Lo sentimos, pero el contenido de esta página es de acceso restringido. ] | |
| Francis Newton Thorpe - 1977 - 764 páginas
[ Lo sentimos, pero el contenido de esta página es de acceso restringido. ] | |
| |